Laura ERNSTERHOFF

Laura ERNSTERHOFF

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Laura ERNSTERHOFF [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 11. April 1894 Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
Bestattung Southgate, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Tod Dezember 1972 [30] [31]
Wohnen 1900 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1910 District 1, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1922 Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1930 Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1935 Southgate, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1940 Southgate, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen vor 1951 New York, USA nach diesem Ort suchen [38]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Southgate, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 23B; Enumeration District: 19-35
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 1, Campbell, Kentucky; Page: 1A; Enumeration District: 0017; FHL microfilm: 2340473
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 512; Page: 10; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 1240512
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: District 1, Campbell, Kentucky; Roll: T624_466; Page: 1B; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 1374479
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Ohio, County Marriages, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 11 Jun 1948; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103283393/?article=ce01f7f6-6161-45c7-ba99-ca5a4be2b142&focus=0.02219077,0.7269397,0.14691214,0.81738615&xid=335
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Southgate, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 23B; Enumeration District: 19-35
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 1, Campbell, Kentucky; Page: 1A; Enumeration District: 0017; FHL microfilm: 2340473
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 512; Page: 10; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 1240512
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: District 1, Campbell, Kentucky; Roll: T624_466; Page: 1B; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 1374479
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Ohio, County Marriages, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 11 Jun 1948; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/103283393/?article=ce01f7f6-6161-45c7-ba99-ca5a4be2b142&focus=0.02219077,0.7269397,0.14691214,0.81738615&xid=335
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 Kentucky, Death Records, 1852-1953, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Southgate, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 23B; Enumeration District: 19-35
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 1, Campbell, Kentucky; Page: 1A; Enumeration District: 0017; FHL microfilm: 2340473
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 512; Page: 10; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 1240512
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: District 1, Campbell, Kentucky; Roll: T624_466; Page: 1B; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 1374479
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Ohio, County Marriages, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 512; Page: 10; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 1240512
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: District 1, Campbell, Kentucky; Roll: T624_466; Page: 1B; Enumeration District: 0010; FHL microfilm: 1374479
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 1, Campbell, Kentucky; Page: 1A; Enumeration District: 0017; FHL microfilm: 2340473
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Southgate, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 23B; Enumeration District: 19-35
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Southgate, Campbell, Kentucky; Roll: m-t0627-01289; Page: 23B; Enumeration District: 19-35
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 Social Security Death Index, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person